USA
Tennessee (cont.)
Rhea, Orlena Tennessee  b. c 1845
Rhea, Pleasant  b. c 1810
Rhea, Robert  b. c 1847
Rhea, William  b. c 1842
Ross, Nancy Nadine  b. 1932, d. 2024
Royster, Sallie H.  b. 1832, d. bt 1900 - 1910
Rust, Della  b. 1880, d. 1946
Rust, Harriett  b. 1864
Rust, Infant twin  b. c 1876, d. c 1876
Rust, Infant twin  b. c 1876, d. c 1876
Rust, Infant twin  b. c 1884, d. c 1884
Rust, Infant twin  b. c 1884, d. c 1884
Rust, Isaac Newton  b. 1847, d. 1891
Rust, James Franklin  b. c 1852, d. 1912
Rust, John C.  b. 1844, d. 1898
Rust, Malinda L.  b. 1841
Rust, Mary E.  b. 1855, d. 1879
Rust, Nancy Dee  b. 1876, d. 1907
Rust, Samuel M.  b. 1845
Rust, William H.  b. 1850, d. 1896
Safley, Elizabeth A.  b. 1830, d. 1912
Satterwhite, Amy Anna  b. 1785, d. 1860
Savage, Thomas Jefferson  b. 1846
Sexton, Gerline  b. 1937, d. 1998
Sims, Caroline  b. c 1840
Sims, Celena  b. 1855, d. 1926
Sims, Charlotte  b. c 1860
Sims, Elisha M.  b. c 1831
Sims, Elizabeth  b. c 1822
Sims, Frances H.  b. c 1836
Sims, Hopkins T.  b. c 1833
Sims, Ida  b. c 1869
Sims, James Turney  b. 1825, d. 1886
Sims, Tirisa J.  b. c 1839
Sims, William  b. 1797, d. 1857
Sims, William P.  b. c 1847
Smith, Rebecca  b. 1836, d. 1900
Smith, Thomas Hunter  b. 1834, d. 1927
Starnes, Cora B.  b. 1875, d. 1947
Stroud, Sallie B.  b. c 1850
Tatum, Lennie
Taylor, Dulin Hassell  b. 1914, d. 2003
Thach, Alfred Taylor  b. 1886
Thach, Alice Gertrude  b. 1888
Thach, Anna C.  b. 1898
Thach, Dan T.  b. 1858
Thach, Effie L.  b. 1884
Thach, Frank L.  b. 1894
Thach, Howard Clayton  b. 1913, d. 1977
Thach, John O.  b. 1892
Thach, Julia Crate  b. 1897
Thach, Lula Evaline  b. 1880, d. 1954
Thach, Minnie Ethel  b. 1884
Thach, Robert T.  b. 1895
Thach, Vernon J.  b. 1889
Threatt, Ennis Miles  b. c 1927, d. 1979
Tiller, Ellender T.  b. c 1849
Tucker, Samuel  b. 1833
Turney, Charlotte  b. 1803, d. 1857
Unknown, Alice E.  b. 1899, d. 1924
Unknown, Anna A.  b. c 1878
Unknown, Francis  b. c 1823
Unknown, Irene  b. 1896, d. 1979
Unknown, Laura  b. 1850
Unknown, Lilly  b. 1881
Unknown, Lucinda  b. c 1823
Unknown, Martha J.  b. c 1833
Unknown, Nannie V.  b. c 1865
Unknown, Sarah D.  b. 1862
Vandergriff, Sarah  b. 1823, d. 1896
Warren, Eliza  b. 1842
Warren, Susanah  b. 1835
Wayne, Spencer Henry
Whitson, Elizabeth  b. c 1797
Wilkey, Christopher Columbus  b. 1841, d. 1918
Wilkey, Rhoda A.  b. c 1844
Wilkey, Samuel  b. c 1817, d. 1871
Wilkey, Samuel A.  b. 1862
Wilkey, Sylvester L.  b. 1846, d. 1912
Williams, Celia Braswell  b. 1853, d. 1920
Wilson, Elizabeth Adaline  b. 1858, d. 1919
Wyatt, Bobby Dean  b. 1941, d. 2006
Wyatt, James Wesley Jr.  b. 1910, d. 1987
York, Minnie Edna  b. 1899, d. 1989
Benton County
Myers, Roby Herbert  b. 1896
Myers, Samuel  b. c 1836, d. 1903
Blount County
Calvert, Sarah  b. c 1780, d. b 1828
Bradley County
Powers, Sydney  b. 1904, d. 1956
Claiborne County
Hatfield, Mary  b. 1885
Hatfield, Moses  b. c 1860
Hatfield, Wilee C.  b. 1889
Shuler, David  b. c 1819, d. a 1865
Shuler, Emaline  b. c 1857, d. 1937
Clay County
Arms, Permilia F.  b. 1853, d. 1919
Bow, Doctor Stover  b. 1848, d. 1917
Bow, Guy Edward  b. 1937, d. 2000
Doyle, Linda Gale
Watkins, Daniel Marion  b. 1890, d. 1929
Cocke County
Godsey, Burley  b. c 1791, d. 1836
Poe, Mary  b. 1801, d. 1881
Coffee County
Cate, Mary Susan  b. c 1804, d. c 1851
Milliken, George Franklin  b. c 1803, d. 1871
Crockett County
Unknown, Alice E.  b. 1899, d. 1924
Davidson County
Alsbrook(s), Sarah Elizabeth  b. 1886, d. 1947
Benedict, Carlene Ann
Butler, Thomas Hunt
Eaton, John W.  d. 1865
Edwards, Madeline Frances
Edwards, Ruth Eleanor  b. c 1922, d. 2010
Griffin, Patrick Martin
Hessey, Ashley T.  b. c 1846, d. 1915
Hessey, Ward Murry  b. c 1898, d. 1957
Hunter, Beulah Cleopatra  b. 1896, d. 1974
Jackson, Bula Lois  b. 1908, d. 1988
Krenson, Richard Gilbert
Milliken, Amos Kendall  b. 1841, d. 1911
Milliken, Ella Louise  b. 1913, d. 1979
Milliken, John Harbison  b. 1874, d. 1959
Milliken, Lucy Alice  b. a 1850
Milliken, Lucy Olive  b. 1851, d. 1914
Milliken, Mary  b. c 1845
Milliken, Mary Elizabeth  b. 1853, d. 1927
Milliken, Phoebe Ellen  b. 1843, d. 1921
Milliken, Robert P.  b. 1855, d. 1934
Milliken, Sandol Humphreys  b. 1877, d. 1918
Milliken, Virginia Lynn  b. c 1919, d. 2009
Milliken, William Alfred (Hon.)  b. 1845, d. 1931
Milliken, Zannie B.  b. 1940, d. 2017
Myers, Roby Herbert  b. 1896
Nuckols, Allyson Clark
Nuckols, Earl Wendell  b. 1919, d. 2003
Pyle, Marietta
Rust, Bulah Lytle  b. 1879, d. 1929
Starnes, Cora B.  b. 1875, d. 1947
Stowers, Katherine  b. 1878, d. 1949
Unknown, Irene  b. 1896, d. 1979
Dickson County
Parker, Abigail  b. 1804
Parker, John  b. 1810
Parker, Sarah  b. 1807
Fayette County
Fayetteville County
Franklin County
Graham, Maurice Yvon  b. 1928, d. 2022
Hessey, Ashley T.  b. c 1846, d. 1915
Hessey, Ashley T.  b. 1908, d. 1992
Hessey, Coleman Clyde  b. 1896, d. 1977
Hessey, Walter M.  b. c 1871
Hessey, Ward Murry  b. c 1898, d. 1957
Hunter, Beulah Cleopatra  b. 1896, d. 1974
Starnes, Cora B.  b. 1875, d. 1947
Stroud, Sallie B.  b. c 1850
Gibson County
Eaves, Andrew David  b. 1857, d. 1943
Grainger County
Butler, Calvin M.  b. c 1834, d. 1890
Greene County
Grundy County
Burnett, John  b. 1830, d. 1903
Burnett, Stephen  b. 1870, d. 1880
Cox, Della  b. 1885, d. 1980
Griswold, Dewitt Clinton  b. 1893, d. 1946
Griswold, Dickie  b. 1898
Griswold, George G.  b. c 1848
Griswold, Lee  b. 1895
Hunter, Beulah Cleopatra  b. 1896, d. 1974
McElroy, Margaret S.  b. 1816, d. 1870
Roberts, Nancy  b. 1807, d. 1878
Rust, Barbara Ellen  b. 1910, d. 1972
Rust, Bulah Lytle  b. 1879, d. 1929
Rust, Christopher Columbus  b. 1874, d. 1926
Rust, Della  b. 1880, d. 1946
Rust, Frank Sims  b. c 1884, d. 1919
Rust, Isaac  b. 1813, d. 1877
Rust, Isaac Newton  b. 1847, d. 1891
Rust, Issac Farris  b. 1879, d. 1956
Rust, James Franklin  b. c 1852, d. 1912
Rust, John C.  b. 1844, d. 1898
Rust, Margaret Evelyn  b. 1859, d. 1913
Rust, Martha Jane  b. 1837, d. 1880
Rust, Mary E.  b. 1855, d. 1879
Rust, Nancy Dee  b. 1876, d. 1907
Safley, Elizabeth A.  b. 1830, d. 1912
Sims, Allie  b. c 1865
Sims, Celena  b. 1855, d. 1926
Sims, Charlotte  b. c 1860
Sims, Ida  b. c 1869
Sims, James Turney  b. 1825, d. 1886
Sims, Peter  b. c 1862
Smith, Margaret Emily  d. 1878
Thomasson, Anna  b. c 1765, d. c 1851
Warren, Eliza  b. 1842
Warren, Thomas  b. 1805, d. 1884
Hamblen County
Butler, Calvin M.  b. c 1834, d. 1890
Hamilton County
Griswold, Dewitt Clinton  b. 1893, d. 1946
Hixson, Babe  b. c 1859, d. b 1870
Hixson, Columbus H.  b. 1892, d. 1930
Hixson, Ephraim  b. 1855, d. 1883
Hixson, Floyd A.  b. 1885, d. 1915
Hixson, Fred Lander  b. 1896, d. 1946
Hixson, James F.  b. 1845, d. 1913
Hixson, Joseph D.  b. 1858, d. 1933
Hixson, Margaret  b. c 1853
Hixson, Nancy  b. 1848, d. 1921
Hixson, Neta N.  b. 1899
Hixson, Sarah L.  b. c 1850
Hixson, Thomas  b. 1863, d. 1942
Hixson, Washington  b. 1825, d. 1908
Hixson, Wilson J.  b. 1855, d. 1907
Hunter, Alabama  b. 1865, d. 1915
Kirkland, Salla Edith  b. 1898, d. 1983
Layne, Charles Reed  b. 1897, d. 1937
Layne, Mary Mable  b. 1893
Layne, Rosa Edith  b. 1892, d. 1960
Layne, Walter DeWitt  b. 1930, d. 2021
Minyard, Homer Herbert  b. 1886, d. 1962
Minyard, John  b. 1854, d. 1944
Potter, Martha
Starr, Samuel Silas  b. 1848, d. c 1902
Thach, Howard Clayton  b. 1913, d. 1977
Vandergriff, Sarah  b. 1823, d. 1896
Wayne, Margaret Ellen  b. 1924, d. 1944
Hardeman County
Sain, Lillie Mae  b. 1885, d. 1971
Hardin County
Eaves, Andrew David  b. 1857, d. 1943
Hardman County
Hawkins County
Riddle, Nathan  b. 1810, d. c 1885
Haywood County
Eaves, Andrew David  b. 1857, d. 1943
Henry County
Brannon, Audie M.  b. 1894, d. 1977
Charles, Robert Coleman  b. 1880, d. 1960
Edwards, James Able  b. 1858, d. 1932
Edwards, James Thurman  b. 1922, d. 1924
Edwards, Joseph A.  b. 1931
Edwards, Martha  b. c 1927, d. b 2010
Edwards, Ruth Eleanor  b. c 1922, d. 2010
Elrod, Willie Mae
Hooper, Mary Annie  b. 1907, d. 1936
Huggins, Pauline  b. c 1903, d. 1985
Milliken, Alonzo Thomas  b. 1845, d. a 1865
Milliken, Amanda Josephine  b. c 1852, d. c 1870
Milliken, Amos  b. 1795, d. 1856
Milliken, Charles John  b. 1857
Milliken, George Melton  b. 1826, d. 1874
Milliken, George Simeon  b. 1869, d. 1870
Milliken, Jennie Porter  b. 1855
Milliken, Martha Helen  b. 1847
Milliken, Nancy Edna  b. c 1853, d. c 1869
Milliken, Oscar Amos  b. c 1866
Milliken, Roe  b. 1880
Milliken, Sarah Elizabeth  b. 1859
Milliken, William Alexander  b. 1849
Milliken, William M.  b. 1824, d. 1896
Norris, John Arthur
Pierce, Mary Virginia  b. 1928, d. 2009
Pierce, William Bryant  b. 1896, d. 1981
Unknown, Sarah
West, Agness  b. 1762, d. 1848
Williams, Elizabeth Ann  b. 1826
Wilson, Elizabeth Adaline  b. 1858, d. 1919
Jefferson County
Johnson
Russell, Rebecca  b. 1782, d. 1875
Knox County
Hallmark, Cummins  b. 1797
Hallmark, John  b. 1776, d. 1840
Hallmark, Mynatt  b. 1793, d. c 1864
Hinds, Eliza Ann  b. c 1811
Mynatt, Leanna  b. 1756, d. 1824
Satterwhite, Amy Anna  b. 1785, d. 1860
Lawrence County
Eaves, Thomas  b. c 1830
Hale, Nancy E.  b. 1868, d. 1961
Kirk, Mary Ann  b. 1852, d. 1874
Milliken, Charles C.  b. 1814, d. 1891
Milliken, Ellen J.  b. 1853, d. 1928
Milliken, James Turner  b. 1849, d. 1918
Milliken, Margaret Anne  b. 1874, d. 1941
Milliken, Margaret Frances  b. 1857, d. 1941
Milliken, Robert Jr.  b. c 1795, d. 1857
Milliken, Robert P.  b. 1855, d. 1934
Milliken, Turner  b. bt 1810 - 1812, d. 1866
Perdue, Cornelia A.  b. 1826, d. 1916
Renfro, John A.  b. 1871, d. 1932
Turner, Christean  b. bt 1775 - 1780, d. bt 1840 - 1850
Unknown, Martha J.  b. c 1833
Lewis County
Bresbois, August  b. 1882, d. 1968
Bresbois, Bertha  b. 1910, d. 1953
Carroll, Melvina M.  b. 1875, d. 1945
Fite, James Thurston  b. 1908, d. 1988
Hale, Nancy E.  b. 1868, d. 1961
Milliken, James Turner  b. 1849, d. 1918
Milliken, Margaret Anne  b. 1874, d. 1941
Milliken, Margaret Frances  b. 1857, d. 1941
Milliken, Mary B.  b. 1879, d. 1882
Milliken, Robert Jr.  b. c 1795, d. 1857
Milliken, Robert P.  b. 1855, d. 1934
Milliken, William Harbeson  b. 1815, d. 1880
Pollock, Louisa Jane  b. 1825, d. a 1870
Tait, Celine C.  b. 1840, d. 1918
Turner, Christean  b. bt 1775 - 1780, d. bt 1840 - 1850
Lincoln County
Bennett, Martha J.  b. c 1858, d. b 1910
Madison County
Adams, Agatha Caroline  b. 1832, d. 1882
Allison, Delaine Victoria  b. 1859, d. 1955
Allison, William Malachai  b. 1798, d. 1876
Allison, William Malachi  b. 1835, d. 1874
Christian, Gilbert I.  b. 1856, d. 1945
Christian, Robert Gilbert  b. 1886, d. 1959
Ellison, Mary  b. 1798, d. 1871
Marion County
Cooley, Lois L.
Hunter, Andrew Jackson  b. 1844, d. 1924
Hunter, Cynthia Ann  b. 1867, d. 1951
Hunter, James Alton Sr.  b. 1901, d. 1978
Layne, Charles Reed  b. 1897, d. 1937
Layne, Grace  b. 1917, d. 2011
Layne, James Andrew  b. 1889, d. 1945
Layne, Mary Mable  b. 1893
Layne, Patrick Martin Jr.  b. 1923, d. 2001
Layne, Patrick Martin Sr.  b. 1902, d. 1951
Layne, Rosa Edith  b. 1892, d. 1960
Layne, Thomas Franklin  b. 1910, d. 1991
Layne, Walter Scott  b. 1906, d. 1967
Layne, William M.  b. 1856, d. 1932
Thach, Lula Evaline  b. 1880, d. 1954
Thach, Martin Luthur  b. 1885
Thach, Millard Fillmore  b. 1855, d. 1939
Wayne, Margaret Ellen  b. 1924, d. 1944
Wilkey, Kizziah L.  b. 1848, d. 1925
Marshall County
Unknown, M. Eva  b. c 1850, d. 1933
Maury County
Cathey, Elizabeth  b. c 1809
Chambers, John  b. c 1832
Chambers, Joseph L.  b. c 1828
Chambers, Mary E.  b. c 1834
Chambers, William
Hunter, John Marshall  b. 1863, d. 1945
Loflin, Eliza M.  b. c 1841
Loflin, Joseph  b. c 1784
Loflin, Josiah Young  b. 1843, d. 1916
Loflin, Malinda J.  b. c 1840
Loflin, Richard B.  b. c 1848
Loflin, Sally W.  b. c 1838
Loflin, Vincent R.  b. c 1845, d. 1922
Pollock, Louisa Jane  b. 1825, d. a 1870
Renfro, John A.  b. 1871, d. 1932
McMinn County
Sneed, Richard Taylor  b. 1853, d. 1905
Womack, Jemima M.  b. 1836, d. 1920
Meigs County
Barrett, Samuel S.  b. 1839, d. 1910
Brock, George Elmore  b. 1860, d. 1919
Clark, Malissa
Godsey, Ishmeal Asberry  b. 1817, d. 1894
Godsey, James L.  b. 1825, d. 1908
Godsey, Sarah Ann  b. 1822, d. a 1880
Hixson, Joseph D.  b. 1858, d. 1933
Hunter, Alabama  b. 1865, d. 1915
Hunter, Amanda C.  b. c 1848
Hunter, Andrew  b. c 1859
Hunter, Bertie L.  b. c 1885
Hunter, Elmore Talvin  b. 1867, d. 1939
Hunter, Floyd Foust  b. 1902, d. 1939
Hunter, George L.  b. c 1864
Hunter, James L.  b. c 1855, d. bt 1881 - 1899
Hunter, John A.  b. c 1857
Hunter, John Marshall  b. 1863, d. 1945
Hunter, Martha  b. c 1845, d. 1899
Hunter, Pleasant  b. c 1844
Hunter, Sarah E.  b. c 1849, d. 1926
Hunter, Selitha  b. c 1848
Hunter, Texas Liruvener  b. 1860, d. 1888
Hunter, Thomas M.  b. c 1785, d. 1850
Hunter, Thomas M. Jr.  b. c 1818, d. a 1880
Hunter, William M  b. c 1853
Poe, Mary  b. 1801, d. 1881
Powers, Charles Floyd  b. 1906, d. 1949
Powers, Cledith Delene  b. 1929, d. 2017
Powers, Thurman Ross  b. 1936, d. 1936
Powers, William Hardin
Smith, Craten Mariah  b. 1869, d. 1948
Smith, Samuel Montgomery  b. 1871, d. 1946
Sneed, Bessie L.  b. 1891
Sneed, Catherine H.  b. 1889
Sneed, Etta M.  b. 1893
Sneed, Georgia Viola  b. 1903, d. 1983
Sneed, Kate E.  b. 1898
Sneed, Mater C.  b. 1893
Sneed, Richard Taylor  b. 1853, d. 1905
Monroe County
Giles, Delila  b. 1862
Kirkland, Charles  b. 1892
Kirkland, James Lafayette  b. 1857
Kirkland, James M.  b. 1888
Kirkland, Jessie  b. 1885
Kirkland, John  b. 1890
Kirkland, Pollie  b. 1894
Kirkland, Salla Edith  b. 1898, d. 1983
Minyard, Homer Herbert  b. 1886, d. 1962
Minyard, John  b. 1854, d. 1944
Montegomery County
Pace, Gloria Elaine  b. 1924, d. 2017
Montgomery County