USA
Texas
Van Zandt County
Daniels, Ruth Leona  b. 1909
Daniels, Walter D.  b. 1882, d. 1958
Donahoe, Minnie
Geddie, Earl Dean  b. 1924, d. 2005
Geddie, Samual Allen  b. 1900, d. 1953
Geddie, William Hiram  b. 1861
Moseley, Lula  b. 1871, d. 1948
Phillips, Willie May  b. 1901
Shaw, Curt  b. 1935, d. 2002
Sublett, Arrie  b. c 1878
Victoria County
Beck, Frank E.  b. 1873, d. 1918
Beck, Oya Idell  b. 1895, d. 1978
Brady, James W.
Broom(e), Mittie E.  b. 1875, d. 1935
French, Jenta  b. 1894, d. 1989
Harrington, Darla
Kemper, Mary Ellen
Key, Marion Henry  b. 1887, d. 1973
Rees, Robert Gregory
Thornton, Nancy Caroline  b. 1829, d. 1920
Tucker, Willie Mae  b. 1917, d. 1986
Webb County
Ojeda, Aurora  b. 1903
Ojeda, Delia  b. 1911, d. 1955
Ojeda, Gabino  b. c 1904, d. 1938
Ojeda, Hilario  b. 1897
Ojeda, Rosa  b. 1905, d. 1963
Rodriguez, Canuta  b. c 1876
Wheeler County
Stephens, Thomas William  b. 1933, d. 2009
Witt, Bonnie Lee  b. 1903, d. 2004
Witt, John Foster  b. 1863, d. 1937
Witt, Sarah Josephine  b. 1894, d. 1962
Wichita
Willacy County
Wise County
Gorman, Eleanor Fay  b. 1918, d. 2005
Latham, Raymond Lewis
Musgrove, Clifton Neil  b. 1892
Musgrove, Curtis Comegys  b. 1901, d. 1990
Musgrove, Felix Andrew  b. 1862, d. 1944
Musgrove, Francis Neil  b. 1900
Musgrove, Jessie Kate  b. 1895, d. 1975
Musgrove, Lee Emmett  b. 1896, d. 1983
Musgrove, Lowell Glenn  b. 1901, d. 1952
Musgrove, Terrell Norris  b. 1898, d. 1979
Reese, Alcy Emmaline  b. c 1844, d. 1920
Young, Eva Lena  b. 1887, d. 1977
Yoakum County
Radford, Ada Eleanor  b. 1889, d. 1989
Tucker, Frank Clebriant  b. 1896, d. 1977
Young County
Gober, Dolores Lea
Graham, Maurice Yvon  b. 1928, d. 2022
Rees, Robert Edwin  b. 1943, d. 2008
Vermont
Addison County
Babson, George Henry  b. 1915, d. 1987
Gibson, Charlotte  b. 1843, d. 1925
Hurlburt, Rose M.  b. 1874
Jordan, Bessie Florence  b. 1895, d. 1938
Jordan, Chester Benjamin  b. 1889, d. 1969
Jordan, Clyde Arthur  b. 1912, d. 1969
Jordan, Cora  b. 1867, d. 1950
Jordan, Elizabeth Ruth  b. 1929, d. 2015
Jordan, Elsie Mae  b. 1910, d. 1983
Jordan, Frederick F.  b. 1870, d. 1926
Jordan, Ralph Herbert  b. 1907, d. 1973
Jordan, Richard William  b. 1921, d. 1984
LaBeau, Alice  b. 1862
Newton, Hollis  b. c 1885
Poquette, Richard Rene  d. 2014
Tredo, Alice  b. 1890
Tredo, Charles  b. 1859
Tredo, Mary A.  b. 1892, d. 1916
Trudeau, Lucy Ursella
Chittenden County
Berry, Johann  b. 1937, d. 2014
Detore, James Vincent  b. 1908, d. 1969
Detore, John Douglas  b. 1935, d. 2015
Detore, Judith Lynn
Detore, Richard Arlyn
Detore, William Chester  b. 1941, d. 1941
Hasbrouck, John Suffern Jr.
Hill, Charles Edwin  b. 1921, d. 1998
Jordan, Addie Marie  b. 1863, d. 1941
Jordan, Chester Benjamin  b. 1889, d. 1969
Jordan, Elsie Mae  b. 1910, d. 1983
Jordan, Gladys Alice  b. 1929, d. 2005
Nelson, Beverly Ann
Poquette, Deborah Jane  b. 1947, d. 2017
Franklin County
LaBeau, Prosper  b. c 1837, d. 1902
Orange County
Hill, Charles Edwin  b. 1921, d. 1998
Jordan, Gladys Alice  b. 1929, d. 2005
Rutland County
Jordan, Chester Benjamin  b. 1889, d. 1969
Tredo, Mary A.  b. 1892, d. 1916
Virginia
Asberry, Jefferson  b. c 1863
Asberry, John  b. c 1867
Asberry, Joseph  b. c 1819
Asberry, Julia I.  b. 1881, d. 1970
Asberry, Lorin  b. 1883
Asberry, Mary Thomas  b. 1885, d. 1974
Bain, Robert M.  b. c 1858
Bonaham, Hannah  b. 1823, d. 1870
Bow, Jacob  b. c 1790, d. b 1860
Bow, Jessee Robinson  b. 1809, d. 1872
Bow, Lucy Ann  b. c 1772, d. c 1796
Dingus, John B.  b. 1863, d. 1904
Ellison, Mary  b. 1798, d. 1871
Gafford, James M.  b. c 1815
Gollahon, Easter Emeline  b. c 1839, d. c 1863
Gregg, Ida M.  b. c 1882
Hall, Mary Polly  b. c 1829, d. 1900
Hallmark, George William Washington  b. 1778, d. c 1852
Jent, Henry  b. c 1819
Lambert, Jordan Wheat  b. 1851
Layne, James Andrew  b. 1889, d. 1945
Leake, Richard  b. c 1691
Milliken, Aileen Burns  b. 1873, d. 1962
Milliken, William Hugh
Morefield, Alex  b. c 1845, d. 1922
Neighbors, Jacob  b. a 1792
Neighbors, John  b. a 1792
Neighbors, William
Norris, Agustus P.  b. c 1879
Parrott, Josiah  b. c 1797, d. bt 1870 - 1880
Rodes, James  b. c 1842
Russell, J. F.  b. a 1811
Rust, Isaac  b. 1813, d. 1877
Shuler, Abraham  b. 1822, d. 1897
Shuler, Absalom  b. c 1836
Shuler, Adam  b. c 1804, d. 1870
Shuler, Archibald  b. c 1846
Shuler, Calvin  b. c 1840
Shuler, Charlton B.  b. c 1827
Shuler, Cleopatra  b. c 1859
Shuler, David  b. c 1819, d. a 1865
Shuler, Emaline  b. c 1857, d. 1937
Shuler, Franklin  b. c 1839
Shuler, James A.  b. 1896
Shuler, James Alexander Hamilton (Rev.)  b. c 1859, d. 1935
Shuler, James K.  b. c 1836
Shuler, James W.  b. c 1843
Shuler, John  b. c 1831
Shuler, John Kendrick  b. c 1797, d. 1878
Shuler, Joseph K.  b. c 1842
Shuler, Louisa  b. c 1838
Shuler, Ludema Elvira  b. 1842, d. 1933
Shuler, Mary  b. 1862, d. 1956
Shuler, Michael  b. c 1810, d. 1855
Shuler, Orlena M.  b. 1862, d. 1929
Shuler, Phebe  b. c 1845
Shuler, Philip Lofton (Rev.)  b. c 1831, d. 1915
Shuler, Stephen  b. c 1837
Shuler, Stephen Leander  b. c 1864
Shuler, Susan  b. c 1832
Shuler, Theresa  b. c 1835
Shuler, Virginia  b. c 1858
Shuler, Wade  b. c 1843, d. 1921
Shuler, Wiley  b. c 1842
Sims, William  b. 1797, d. 1857
Stanley, Anderson  b. 1782, d. 1831
Stanley, Elizabeth  b. 1787, d. 1827
Stanley, John W.  b. 1790, d. 1817
Stanley, Unity  b. 1780, d. 1834
Thurman, Rachel  b. c 1778, d. 1868
Todd, Katia Amelia
Unknown, Elizabeth  b. c 1692, d. c 1784
Unknown, Emily J  b. c 1850
Unknown, Lois E.  b. c 1835
Westfall, Samuel  b. c 1778, d. c 1852
Winn, Elizabeth Liscome  b. 1853
Wortham, Elizabeth  b. c 1785, d. a 1813
Wortham, Frances Benjamine  b. c 1781, d. 1880
Wortham, Samuel Ironsides  b. 1784, d. 1867
Wortham, Thomas C.  b. c 1779, d. a 1816
Young, William Barnes (Colonel)  b. 1813, d. 1893
Albemarle County
Busch, Sallie Marie  b. 1931, d. 2001
Wheeler, Kenneth Mason  b. 1928, d. 2021
Botetourt County
Hallmark, John  b. 1776, d. 1840
Buckingham County
Godsey, Augustine Austin  b. c 1752, d. c 1818
Godsey, Burley  b. c 1791, d. 1836
Godsey, Burton  b. 1782, d. 1862
Godsey, Elizabeth  b. c 1781, d. bt 1781 - 1782
Godsey, John  b. 1783, d. 1868
Godsey, Thomas  b. c 1715, d. a 1780
Godsey, William  b. c 1758, d. 1831
Godsey, William Jr.  b. 1780
Hensley, Agnes  b. c 1763, d. bt 1840 - 1850
Hicks, Frances  b. c 1760, d. 1855
Campbell County
Radford, William  b. 1782, d. 1862
Chesterfield County
Coxe, John  b. c 1708, d. 1795
Culpeper County
Hord, Harriet Louisa  b. 1821, d. 1871
Culpepper County
Parker, Daniel (Elder)  b. 1781, d. 1844
Parker, John (Elder)  b. 1758, d. 1836
White, Sarah  b. c 1759, d. c 1824
Fluvanna County
Giles County
Shuler, Samuel M.  b. 1841, d. 1862
Gloucester County
Burch, William  b. 1706
Goochland County
Bow, Oney P.  b. c 1764, d. a 1798
Parrott, Tyree
Grayson County
Allen, Carr  b. 1786, d. a 1868
Anderson, Margaret
Bonaham, Hannah  b. 1823, d. 1870
Bonaham, Joseph  b. c 1798, d. 1881
Cornett, George Lloyd
Hackler, Mary S.  b. c 1831
Hall, Elizabeth  b. 1804, d. 1880
Luellen, Adam  b. 1830
Myers, Charity Anna  b. 1769, d. 1856
Russell, Ann  b. c 1804, d. 1896
Russell, Phillip  b. 1775, d. 1839
Russell, Phoebe  b. 1810, d. 1865
Russell, Rebecca  b. 1782, d. 1875
Russell, Tabitha L.  b. c 1805, d. 1887
Shuler, Adam  b. c 1804, d. 1870
Shuler, Catherine  b. a 1839
Shuler, Elbert Riley  b. 1858, d. c 1945
Shuler, George Michael  b. 1805, d. 1869
Shuler, Hensley Powell  b. 1856, d. 1864
Shuler, Ludema Elvira  b. 1842, d. 1933
Shuler, Mary  b. 1862, d. 1956
Shuler, Mary Polly  b. c 1829
Shuler, Michael  b. c 1810, d. 1855
Shuler, Michael Nicholas Jr.  b. 1759, d. 1862
Shuler, Philemon  b. c 1842, d. c 1870
Shuler, Philip Lofton (Rev.)  b. c 1831, d. 1915
Shuler, Rosamond Casada  b. 1843
Shuler, Samuel M.  b. 1841, d. 1862
Shuler, Sarah E.  b. 1862, d. 1865
Wright, Jeff
Henrico County
Lee County
Asberry, Esta Francis  b. 1879, d. 1954
Asberry, Rebecca  b. c 1864
Asberry, Thomas B.  b. 1858
Fannon, Briant
Freeman, Dona M.
Hall, Elizabeth  b. 1804, d. 1880
Hall, Mary Polly  b. c 1829, d. 1900
Luellen, Marguerete Jane  b. 1857, d. 1939
Morefield, Alex  b. c 1845, d. 1922
Morefield, Rebecca  b. 1896, d. 1957
Shuler, Catherine
Shuler, George W.H.  b. 1893
Shuler, Hamon  b. 1864, d. 1921
Shuler, Martha Jane  b. 1854
Shuler, Mary Lee
Shuler, Orlena M.  b. 1862, d. 1929
Shuler, Robert
Shuler, Valeria Jane  b. 1894, d. 1973
Shuler, Verna Ellen  b. 1891, d. 1934
Wells, Jeremiah C. Jr.
Louisa County
Bow, Jacob  b. c 1740, d. 1782
Lunenburg County
Newton, Henry  b. 1728
Newton, John  b. 1750, d. 1799
Marshall County
Powell, Elvira C  b. 1830, d. 1874
Middlesex County
Grymes, Anne  b. c 1707, d. c 1761
Wortham, George Jr.  b. 1699, d. c 1752
Wortham, John  b. c 1627, d. 1692
Montgomery County
Godsey, James  b. 1791, d. 1868
Patrick County
Pittsylvania County
Bow, Henry  b. c 1755, d. c 1847
Bow, Jesse  b. a 1755
Bow, Lucy Ann  b. c 1772, d. c 1796
Bow, Molly Morris  b. c 1776
Bow, Nathaniel  b. c 1770, d. 1835
Bow, Oney P.  b. c 1764, d. a 1798
Bradley, John
Hester, Mary
Thurman, Laban
Thurman, Rachel  b. c 1778, d. 1868
Thurman, Rhoda
Rockingham County
Powell, Elvira C  b. 1830, d. 1874
Russell County
Scott County
Ayers, Orlando Alexander  b. c 1872
Godsey, Augustine Austin  b. c 1752, d. c 1818
Godsey, James  b. 1791, d. 1868
Godsey, John  b. 1783, d. 1868
Hicks, Frances  b. c 1760, d. 1855
Norris, Laura C.  b. c 1878
Smyth County
Hackler, Mary S.  b. c 1831
Shuler, Wade  b. c 1843, d. 1921
Tazewell County
Gillespie, Nancy Bowen  b. 1824, d. 1862
Young, Emily  b. 1849, d. a 1921
Young, Henry Bowen  b. 1853, d. 1872
Young, Joseph S.  b. 1846, d. 1914
Young, Louvicie Barnes  b. 1844, d. 1907
Young, Margaret Crockett  b. 1850, d. 1932
Young, Robert  b. 1857, d. b 1869
Young, Thomas Gillespie  b. 1843, d. 1917
Young, William Barnes (Colonel)  b. 1813, d. 1893
Washington County
Godsey, Drury Lacy  b. 1795, d. 1873
Godsey, Elizabeth  b. c 1804
Godsey, Harriett  b. c 1806
Godsey, Henry Howard  b. c 1800
Godsey, Jeremiah  b. c 1799, d. a 1880
Godsey, Martin  b. c 1801
Godsey, Samuel  b. c 1802
Godsey, Sarah  b. c 1790
Wise County
Morefield, Rebecca  b. 1896, d. 1957
Washington
Argabright, Elaine Clara  b. 1926, d. 2010
Beam, Charles Lyle  b. 1916, d. 1968
Blakely, Melvin
Brager, Floyd Earl  b. c 1925, d. c 1974
Buckinger, Jean M.  b. 1932, d. 2009
Jones, Irene Jane  b. 1911, d. 2009
Romick, Marie Louise  b. 1918, d. 2020
Clallam County
Beam, Charles Lyle  b. 1916, d. 1968
Jones, Edith M.  b. 1885, d. 1971
Romick, Marie Louise  b. 1918, d. 2020
King County
Beam, Charles Lyle  b. 1916, d. 1968
Buckinger, Jean M.  b. 1932, d. 2009
Gideon, Mary I.  b. 1921, d. 2006
Haarsaker, Dale Allyn
Jones, Edna Margaret  b. 1898, d. 1976
Opstedal, Anthony J.
Romick, Marie Louise  b. 1918, d. 2020
Washington District of Columbia
Milliken, Robert Campbell  b. 1861, d. 1937
West Virginia
Rodes, Aldine J  b. c 1874
Rodes, Anna E.  b. c 1877
Rodes, Harvey J.  b. c 1872
Rodes, James  b. c 1842
Unknown, Emily J  b. c 1850
Berkeley County
Burns, Elizabeth Owings  b. 1838, d. 1934
Fayette County
Kanawha County
Slawter, Betty Lee  b. 1930, d. 2004
Raleigh County
Allen, Carr  b. 1786, d. a 1868
Wisconsin
Brown, Brandon  b. 1988, d. 2022
Llewellyn, Edith Wynn  b. 1874, d. 1917
McCullick, Arnold  b. c 1917, d. 1979
Ochs, Elizabeth Anne  b. 1863, d. bt 1920 - 1930
Columbia County
Crawford County
Crogan, Richard
McCullick, Anna Marie  b. 1939, d. 2017
McCullick, Arlene R.  b. 1947, d. 2003
Paulson, Marion  b. 1917, d. 2004
Dane County
McCullick, Arlene R.  b. 1947, d. 2003