USA
Alabama
Alsbrook(s), James P.  b. c 1860
Box, Eliza Jane  b. 1835
Bristol, George Edward  b. 1891
Bristol, Joseph Dickson  b. 1893
Bristol, Mary Agnes  b. 1889, d. 1931
Brooks, Marthenia  b. 1819, d. 1897
Brown, Annie Alsendy  b. 1880, d. 1961
Bryant, Elizabeth J.  b. 1824
Butler, Martha Izora  b. 1853
Chancellor, Amanda Elizabeth  b. c 1847, d. 1920
Chancellor, Daniel Jackson  b. c 1837, d. 1913
Chancellor, David G.  b. c 1845
Chancellor, George H.  b. c 1834
Chancellor, Jessee D.  b. c 1849
Chancellor, John B.  b. c 1829
Chancellor, King R  b. 1830, d. 1912
Chancellor, Martha M.  b. c 1843, d. 1916
Chancellor, Mary F.  b. 1832, d. 1912
Chancellor, Sarah H.  b. c 1836
Chancellor, William G  b. c 1841
Conkle, Marion William Brantly  b. 1876, d. 1960
Copeland, Mary Jane  b. c 1848
Crow, Warren Baker III  b. 1930, d. 2007
Dorn, John Melvin  b. 1850, d. 1937
Graham, Jesse Byron Jr.  b. 1920, d. 2005
Graham, Maggie P.  b. c 1886
Graham, Nancy C.  b. c 1876
Graham, Walter W.  b. c 1888
Graham, William Bradford  b. 1844, d. 1922
Grant, Opha Cordelia  b. 1896, d. 1980
Grant, Walter C.  b. c 1879
Hallmark, John B.  b. c 1810
Hallmark, Mathew Dewey Thomas  b. 1820, d. c 1906
Ham, America Emiline  b. 1851, d. 1901
Ham, Emma Marinda  b. 1865
Ham, Henry Russell  b. 1845, d. 1899
Ham, Martha Lucretia Jane  b. 1841, d. 1919
Ham, Mary  b. c 1877
Ham, Nancy Malinda  b. 1843
Ham, Pervy  b. c 1875
Ham, Taylor McDondle  b. 1866, d. 1956
Ham, William Gaines  b. 1850
Hinds, William S.  b. 1828, d. 1923
Jones, Mary Ann  b. 1820, d. 1882
Morrow, Luther Elisha  b. 1888, d. 1936
Murray, Catherine
Musgrove, Alexander N.  b. 1836, d. 1912
Perry, Frank  b. 1839
Pierce, Lucy  b. c 1844
Pinson, Sarah  b. 1780, d. 1850
Pruitt, Elizabeth A.  b. c 1835
Rand, F. Pheraba  b. c 1859
Rees, Samuel M.  b. 1850, d. 1894
Reese, Aaron J.  b. c 1831
Reese, Alcy Emmaline  b. c 1844, d. 1920
Reese, Ann  b. c 1854
Reese, David C.  b. c 1848
Reese, Henry C.  b. c 1837
Reese, Nancy C.  b. c 1839
Reese, Penenay J.  b. c 1842
Reese, Rutha J.  b. c 1846
Reese, Sarah E.  b. c 1840
Reese, Terrell M.  b. c 1830
Reese, William D.  b. c 1834
Reeves, Joseph H.  b. 1842, d. 1920
Richardson, Hiram  b. c 1819, d. b 1900
Richardson, Larry Dwight  b. c 1945, d. 2011
Sanders, Emma J.  b. c 1855
Smith, Lewis Franklin  b. 1842
Thompson, John Amstrong  b. 1832, d. 1864
Unknown, Sarah  b. 1852
Walker, Isaiah B.  b. c 1834
Walker, Jane  b. 1932, d. 2016
White, Mary E.  b. c 1860
Wilson, Angie L.D.  b. 1866
Benton County
Brooks, Marthenia  b. 1819, d. 1897
Burch, Birman Dottie  b. 1844, d. 1917
Burch, Reuben  b. 1780, d. 1857
Burch, Thomas  b. 1810, d. 1881
Blount County
Hallmark, Alfred M.  b. 1817, d. 1880
Hallmark, Mynatt  b. 1793, d. c 1864
Bullock County
Dorn, Arthur Ansley  b. 1874, d. 1931
Dorn, Emma  b. 1886, d. 1968
Dorn, Hannah Pauline  b. 1873, d. 1969
Dorn, Ida  b. 1886, d. 1958
Dorn, James Wright  b. 1877, d. 1934
Dorn, John Marvin  b. 1879, d. 1968
Dorn, Lois Delilah  b. 1884, d. 1967
Dorn, Nancy Addrene  b. c 1872, d. c 1873
Dorn, Sarah LeeAnn  b. 1876, d. 1876
Dorn, Una Palestine  b. 1882, d. 1967
McCreless, Talvy Ann  b. 1850, d. 1925
Calhoun County
Newton, Isaac Mitchell  b. 1811, d. 1865
Cherokee County
Brown, Annie Alsendy  b. 1880, d. 1961
Conkle, Marion William Brantly  b. 1876, d. 1960
Clay County
Colbert County
Cullman County
Grant, Opha Cordelia  b. 1896, d. 1980
Morrow, Luther Elisha  b. 1888, d. 1936
Dallas County
Langley, Numan Charles  b. 1888, d. 1961
Dekalb County
Graham, Abel Devon  b. 1814, d. 1896
Graham, Jesse Byron  b. 1892, d. 1978
Etowah County
Walker, Jane  b. 1932, d. 2016
Fayette
Ham, Henry Russell  b. 1845, d. 1899
Reese, Alcy Emmaline  b. c 1844, d. 1920
Fayette County
Musgrove, Erastus James  b. 1868, d. 1931
Musgrove, Felix Andrew  b. 1862, d. 1944
Musgrove, Houston Gaines Sr.  b. 1865, d. 1940
Franklin County
Dickson, Mary Fountain  b. 1859, d. 1927
Moody, Mary Lavinia  b. 1823
Greene County
White, John Andrew  b. c 1840, d. 1894
Lawrence County
Milliken, Alfred (Dr.)  b. 1811, d. 1840
Limestone County
Madison County
Marengo County
Wortham, Elizabeth  b. c 1785, d. a 1813
Marion County
Musgrove, Lizzie  b. 1878, d. 1957
Reese, Seletha C.  b. c 1850
Marshall County
Wilkey, William D.  b. 1868, d. 1944
Mobile County
Bristol, Mary Agnes  b. 1889, d. 1931
Perry County
Radford, Ebeniezer Duval  b. 1844, d. 1922
Radford, William  b. 1782, d. 1862
Radford, William Tarpley  b. 1821, d. c 1855
Pike County
Thompson, John William  b. 1853, d. 1922
Randolph County
Willingham, Iona  b. 1926, d. 2013
Willingham, Mattie Jo  b. 1921, d. 2010
Talladega County
Walker County
Isbell, Keener Reagan (Rev.)  b. 1885, d. 1948
Arizona
Clark, Brian Robert  d. 2015
Curtis, Meta G.  b. 1926, d. 1992
Patraw, Robert William  b. 1921, d. 2001
Poquette, Deborah Jane  b. 1947, d. 2017
Maricopa County
Conkle, Loretta Dale  b. 1942, d. 2005
Jordan, Gladys Alice  b. 1929, d. 2005
Talbert, Franklin D.  b. 1933, d. 1988
Pima County
Jordan, Elsie Mae  b. 1910, d. 1983
Arkansas
Bennett, Robert Hunter  b. 1870, d. 1934
Bristol, Robert Forest  b. 1898
Broomfield, Benjamine Franklin  b. 1894, d. 1982
Browder, Nancy Jane  b. c 1864, d. 1901
Cody, Nora Callie  d. b 1930
Eaves, Andrew David  b. 1857, d. 1943
Eaves, Franklin P.  b. 1889
Eaves, George W.  b. 1885
Eaves, Hattie M.  b. 1898
Eaves, John T.  b. 1896, d. 1978
Eaves, L.D.  b. 1894
Eaves, Matilda May  b. 1891
Eaves, Mintha V.  b. 1883
Eaves, Samuel W.  b. c 1880
Eaves, Tom F.  b. 1881
Eaves, William D.  b. 1893
French, Hugh  b. 1901, d. 1983
Hunter, Emma A.  b. 1874, d. 1921
Hunter, John Wesley  b. 1876, d. 1918
Lightner, Georgia L.  b. 1891
Milliken, George Franklin  b. c 1803, d. 1871
Unknown, Margaret Coldona  b. c 1864
Unknown, Nannie  b. c 1845
Unknown, Rachael  b. c 1856
Williams, Marie  b. 1904, d. 1997
Witt, Mary M.  b. c 1873
Wortham, Sarah Ann  b. 1836, d. 1907
Boone County
McDaniel, Robert Levelle  b. 1909, d. 1981
Garland County
Watson, Jacqueline  b. 1943, d. 2012
Watson, William Hobbs  b. c 1865
Watson, William Jackson  b. 1897, d. b 2012
Watson, William Jackson Jr.  b. c 1940, d. b 2012
Witt, Mary M.  b. c 1873
Hempstead County
King, Benjamin Franklin  b. 1871, d. 1929
Little River County
Broomfield, Benjamine Franklin  b. 1894, d. 1982
Broomfield, Dorothy  b. 1915, d. 1999
Hunter, Emma A.  b. 1874, d. 1921
Polk County
Cooper, Luetta  b. 1888, d. 1965
Pulaski County
Treace, Bertha Ethel  b. 1898, d. c 1974
Scott County
Barrett, Samuel S.  b. 1839, d. 1910
Broomfield, Albert S.  b. 1870
Hunter, Emma A.  b. 1874, d. 1921
Hunter, Sarah E.  b. c 1849, d. 1926
Searcy County
French, Hugh  b. 1901, d. 1983
Sevier County
Humphreys, Ruby Lee  b. 1911, d. 1994
McDaniel, Robert Levelle  b. 1909, d. 1981
Smith County
Stone County
Hegenbart, Patrick Noel  b. 1952, d. 2012
Union County
Black, Melinda Jane  b. 1851, d. 1936
Washington County
White County
French, Charles  b. 1937, d. 2000
French, Hugh  b. 1901, d. 1983
Yell County
Brashear, Malissa Adeline  b. c 1856
Hunter, James L.  b. c 1855, d. bt 1881 - 1899
Hunter, John Wesley  b. 1876, d. 1918
Hunter, Madora  b. 1878, d. 1936
Hunter, Mariah Jane  b. c 1856
Hunter, Sanore  b. 1879
Stafford, Della A.  b. 1877
California
Contra Costa County
Babson, George Henry  b. 1915, d. 1987
Freestone County
Richardson, Charles Bradley  b. 1912, d. 1947
Fresno County
Los Angeles
Boles, John Abram  b. 1888, d. 1973
Marion County
Placer County
Herrmann, Walter E.  b. 1963, d. 2019
Riverside County
Alexander, William Robert  b. 1929, d. 1997
Curtis, Nancy Dolores  b. 1937, d. 1990
Skurzynski, Stanley Joseph  b. 1933, d. 1997
San Bernadino
Hegenbart, Patrick Noel  b. 1952, d. 2012
San Francisco County
San Joaquin County
Stanislaus County
Ham, Elsie Delila  b. 1894, d. 1975
McLaughlin, Raymond R.  b. c 1919, d. 1980
Ventura County
Colorado
Denver County
Brown, Kate Jane  b. 1881, d. 1939
Eastham, Edward Barton  b. 1873, d. 1950
King, Josephus Arthur  b. 1928, d. 2013
Commonwealth of Massachusetts
District of Maine
Tuttle, Thomas C.  b. c 1814
Connecticut
Burlock, Mary de Forest  b. c 1850, d. a 1930
Camp, Walter Jr.  b. 1891, d. 1940
Gilbert, Esther Ann  b. 1819
Goethals, Peter Randall (Dr.)  b. 1926, d. 2000
Keller, George Henrik  b. 1931, d. 2018
Milliken, Sandol Humphreys  b. 1877, d. 1918
Stoddard, Abiram (Dr.)  b. 1777, d. 1855
Stoddard, Carlos French  b. 1880, d. 1933
Stoddard, Francis Eunice  b. 1840
Stoddard, Mary DeForest  b. 1907, d. 1993
Stoddard, Samson  b. 1752, d. 1809
Stoddard, Sarah G.  b. 1842
Stoddard, Thomas (Dr.)  b. 1813, d. 1887
Wright, Hester  b. 1750, d. 1832
Hartford County
Camp, Walter Chauncey  b. 1859, d. 1925
Kaplan, Ziona Goldstein
Keller, Georg Einer G.  b. 1901, d. 1976
Keller, George Henrik  b. 1931, d. 2018
Swift, Katharine Faulkner  b. 1897, d. 1993
Weber, Saul  b. c 1915, d. 2001
Litchfield County
Stoddard, John  b. 1730, d. 1795
Stoddard, Samson  b. 1752, d. 1809
New Haven County
Bowling, David Floyd
Camp, Walter Jr.  b. 1891, d. 1940
Curry, Diane Jacqueline
English, Frances  b. 1889, d. 1929
Harris, Caroline Lyons  b. 1905, d. 1987
Schoellkopf, George Henry  b. 1894, d. 1915
Stoddard, Abiram (Dr.)  b. 1777, d. 1855
Stoddard, Carlos French  b. 1880, d. 1933
Stoddard, Carlos French Jr.  b. 1905, d. 1987
Stoddard, Esther Ann  b. 1874, d. 1951
Stoddard, Ezekiel Gilbert  b. 1844, d. 1923
Stoddard, Louis Ezekiel  b. 1878
Stoddard, Thomas (Dr.)  b. 1813, d. 1887
New London County
Lane, Jesse  b. 1746, d. 1819
Wright, Hester  b. 1750, d. 1832
Tolland County
Keller, George Henrik  b. 1931, d. 2018
Florida
Boles, Ralph Olan  b. 1906, d. 1979
Bullard, Loral Darwin  b. 1921, d. 2004
DeLong, Francis E.  b. 1916, d. 1987
Hart, William C.  b. 1860
Ortenzi, John Rocco Jr.  b. c 1946, d. 2012
Shuler, Joyce Maxine  b. 1923, d. 2000
Taylor, Dick K.  b. 1949, d. 2017