USA
Kentucky
Marshall County
Milliken, George Melton  b. 1826, d. 1874
McCracken County
Gholson, Elizabeth Angeline  b. 1831
Gholson, Phebe Jane  b. 1837, d. 1856
Hord, Harriet Louisa  b. 1821, d. 1871
McClure, Mary Amanda  b. 1834
Milliken, Benjamin Hord  b. 1844, d. 1924
Milliken, Dewitt Clinton  b. a 1825, d. bt 1860 - 1864
Milliken, Edmonia  b. 1852
Milliken, Erastus G.  b. 1822, d. 1894
Milliken, John  b. 1815, d. 1861
Milliken, John S.  b. a 1853, d. 1857
Milliken, John Thomas  b. 1852, d. 1919
Milliken, Josephine  b. c 1835
Milliken, Lynn Boyd  b. 1847, d. 1854
Milliken, Mahala  b. c 1818, d. 1857
Milliken, Margaret Caroline  b. 1855, d. 1925
Milliken, Martin Harbison  b. 1824, d. 1857
Milliken, Samuel Ramsey (Capt.)  b. 1817, d. 1898
Milliken, Spencer  b. c 1820, d. bt 1860 - 1864
Milliken, Ulysses  b. 1831, d. 1870
Milliken, William  b. a 1830, d. 1856
Milliken, William Dickerson Sr.  b. 1848, d. 1916
Milliken, William Norton  b. 1857, d. 1885
Ramsey, Elizabeth  b. c 1796, d. a 1880
Ramsey, Nancy  b. 1795, d. 1877
Watson, Andrew J. (Dr.)  b. c 1830
McCrackern County
Gray, Samuel  b. 1860
Keller, Ama  b. c 1855
Keller, Amanda  b. c 1859
McElrath, Viola  b. c 1839
Milliken, Elizabeth  b. c 1825
Milliken, Spencer  b. a 1794, d. a 1835
Menifee County
McGlothen, Geneva  b. c 1920, d. 2004
Nelson County
Suite, Susannah  b. 1775, d. 1820
Ohio County
Douglas, James Wayne  b. 1938, d. 2011
Pendleton County
Boles, Abraham  b. 1818, d. 1872
Boles, Harmon W.  b. 1841, d. 1913
Moore, Lurana  b. c 1824
Pulaski County
Massie, Manerva Ellen  b. 1824, d. 1878
Rowan County
Simpson County
Bradshaw, Sarah Josephine  b. 1867, d. 1944
Gregory, Jeffery Scott
Hail, Eliza Thompson  b. 1818, d. 1881
Jones, Mallie L.
Leaton, Nancy  b. 1808, d. 1882
Milliken, Albertine Louisa  b. 1920, d. 1947
Milliken, Amos Kendall  b. 1841, d. 1911
Milliken, Annie Melvina  b. c 1856, d. 1940
Milliken, Benjamin Harbeson (Dr.)  b. 1841
Milliken, Caroline  b. a 1812
Milliken, Charles Duncan  b. 1907, d. 1984
Milliken, Charles W.  b. c 1861, d. 1927
Milliken, Charles William  b. 1864, d. 1950
Milliken, Charles William  b. 1905, d. 1996
Milliken, Charles William (Hon.)  b. 1827, d. 1915
Milliken, Elizabeth McDonald  b. 1844, d. 1869
Milliken, Fannie  b. a 1853
Milliken, Floyd Gilbert  b. 1909, d. 1978
Milliken, Floyd Neely  b. 1865, d. 1945
Milliken, George H. (Hon.)  b. 1808, d. 1884
Milliken, Harbison  b. a 1812
Milliken, James  b. 1782, d. 1863
Milliken, James H. (Dr.)  b. 1831, d. 1913
Milliken, James Meachum  b. 1839, d. 1861
Milliken, James Sanford  b. 1868, d. 1939
Milliken, James Stowers  b. 1901, d. 1982
Milliken, James William  b. 1942, d. 1996
Milliken, Jane Agness  b. 1810, d. 1894
Milliken, Jesse (Dr.)  b. c 1790, d. c 1834
Milliken, John (Rev.)  b. a 1807, d. a 1834
Milliken, John Harbison  b. 1874, d. 1959
Milliken, John Harbison Jr.  b. 1923, d. 1999
Milliken, John Hiso  b. 1855, d. 1928
Milliken, John Jesse (Honorable)  b. 1856
Milliken, John Neely Sr.  b. 1904, d. 1971
Milliken, John Robert (Dr.)  b. 1836, d. 1891
Milliken, Joseph Desha  b. c 1839, d. 1840
Milliken, Mary  b. a 1812, d. a 1830
Milliken, Mary Proctor  b. 1915, d. b 1999
Milliken, Mattie Mae  b. c 1885, d. 1952
Milliken, Myra Lee
Milliken, Narcissa  b. a 1812
Milliken, Robert Franklin  b. 1811, d. 1889
Milliken, Robert Minor  b. 1880, d. 1938
Milliken, Susan Elizabeth  b. 1831, d. 1853
Milliken, Thomas Henry  b. 1870, d. 1924
Milliken, Thomas Henry  b. 1913, d. 1945
Milliken, William  b. 1785, d. 1847
Milliken, William West  b. 1806, d. 1883
Myers, Edna Beatrice  b. 1921, d. 2005
Neely, Elizabeth Ann  b. 1843, d. 1922
Ogles, Howard H.  b. c 1913, d. 2007
Rogers, Mary Louise  b. 1914, d. 1996
Royster, Sallie H.  b. 1832, d. bt 1900 - 1910
Scott, Gilbertine Alicia  b. 1904, d. 1972
Stanley, Solomon  b. 1755, d. 1836
Stanley, Unity  b. 1780, d. 1834
Taylor, Dulin Hassell  b. 1914, d. 2003
Vaughan, Senora
West, Elise A.  b. 1782, d. 1857
West, Mary  b. 1791, d. 1851
Todd County
Christian, Charles G.  b. 1855, d. 1935
Douglas, James Wayne  b. 1938, d. 2011
Miller, Brenda Sue  b. 1942, d. 2017
Milliken, Benjamin Hord  b. 1844, d. 1924
Milliken, Mary Louise  b. c 1872, d. 1936
Milliken, William DeWitt Jr.  b. 1922, d. 2012
Mimms, Sallie M.  b. 1855
Morton, Mary M.  b. 1884
Pace, Gloria Elaine  b. 1924, d. 2017
Pace, John Barker  b. 1894, d. 1983
Porter, Mary E.  b. 1827, d. 1872
Wells, Mary P.  b. 1882
Wells, Mary Rebecca  b. 1847, d. 1890
Wells, Samuel Horace  b. 1849
Wells, William Horace  b. 1820, d. 1854
Trigg County
Morris, Gracie  b. c 1892, d. 1965
Warren County
Brock, Wilton  b. c 1805, d. c 1845
Crow, Warren Baker IV
Estes, Joseph Earl  b. c 1922, d. 2005
Hale, Amy Beth
Hayes, Irene  b. 1924, d. 2021
Hayes, James L.  b. 1856, d. 1930
Hayes, Robert Leslie  b. 1887, d. 1967
Hicks, Katherine
Johnson, Ina Merritt  b. 1901, d. 1979
McGlothen, Geneva  b. c 1920, d. 2004
Miller, Ruth  b. c 1922, d. 2011
Milliken, Alfred M.  b. 1855, d. 1876
Milliken, Clarence E.  b. 1883, d. 1883
Milliken, George Duncan Sr.  b. 1877, d. 1967
Milliken, George Hugh Sr.  b. 1893, d. 1956
Milliken, George Wesley  b. 1829, d. 1863
Milliken, George Wesley  b. 1861, d. 1905
Milliken, John Mottley (Judge)  b. 1918, d. 2011
Milliken, Joseph Gilbert
Milliken, Margaret C.  b. 1918, d. 1980
Milliken, Nan Mottley
Milliken, Roy  b. 1898
Milliken, Ruth  b. 1890
Milliken, Virginia Lynn  b. c 1919, d. 2009
Milliken, Wesley Vernon
Milliken, William DeWitt Jr.  b. 1922, d. 2012
Milliken, William DeWitt Sr.  b. 1885, d. 1964
Milliken, Wilton Brock  b. 1858, d. 1899
Nuckols, Edwin Irl  b. 1886, d. 1926
Osborne, Mary Judith  b. c 1940, d. 2021
Perkins, Luella Macpherson  b. 1859, d. 1937
Rogers, Helen  b. c 1921, d. 2012
Whitesides, Walter  b. b 1873
Williams, Louisa Harris  b. 1816, d. 1882
Witt, John Foster  b. 1863, d. 1937
Woodford County
Louisiana
Bishop, Mary E.  b. c 1890
Brinkley, Malissa M.  b. c 1848
Magee, Mandy  b. c 1851
Solomon, George N.  b. c 1866
Unknown, Elizabeth Ellen  b. c 1852, d. c 1894
Walker, Andrew  b. c 1858
Walker, Berelda  b. c 1846
Walker, Caroline E.  b. c 1847
Walker, Ellen  b. c 1851
Walker, Joseph  b. 1854
Walker, Talitha Cumi  b. 1849, d. 1942
Walker, William Daniel  b. c 1850
Beauregard Parish
McDaniel, Doyle Dean  b. 1930, d. 1982
Jackson Parish
Broomfield, Dorothy  b. 1915, d. 1999
McDaniel, Robert Levelle  b. 1909, d. 1981
Orleans Parish
Hunter, Kenneth Dee  b. 1926, d. 2016
Milliken, Vera Lee  b. 1926, d. 2012
Ouachita Parish
Curry, James Jefferson  b. 1883, d. 1960
Sabine Parish
Currie, Addison Earl  b. 1918, d. 1967
Westfall, Samuel  b. c 1778, d. c 1852
Winn Parish
Maine
Hancock County
Sturges, Howard Okie  b. 1845, d. 1920
Washington County
Babson, Henry H.  b. 1892, d. 1955
Maryland
Dorsey, Francis  b. 1741, d. 1769
Keller, Isaac  b. c 1820
Murray, M.J.  b. c 1851
Ortenzi, John Rocco Jr.  b. c 1946, d. 2012
Ortenzi, John Rocco Sr.  b. 1918, d. 2003
Baltimore County
Dorsey, Francis  b. 1741, d. 1769
Simpson, Rachel  b. 1751, d. 1817
Saint Mary's County
Reeves, Joseph H.  b. 1842, d. 1920
Michigan
Barnett, Hattie E.  b. c 1874
Bullard, Loma E.  b. 1922, d. 2007
Bullard, Loral Darwin  b. 1921, d. 2004
Curtis, Meta G.  b. 1926, d. 1992
Curtis, Nancy Dolores  b. 1937, d. 1990
Laine, Ester Clyde Jr.  b. 1924, d. 2012
Layne, Mary Ruth
Llewellyn, Edwin  d. 2002
Prindle, Donna Jean  b. 1920, d. 2006
Raycraft, Burr  b. 1881, d. 1964
Raycraft, John W.  b. 1886
Thayer, Louisa J.  b. c 1843
Bay County
Bullard, Harry Norman  b. 1897, d. 1944
Calhoun County
Shank, William F.  b. 1899, d. 1954
Eaton County
Boles, Harold W.  b. 1915, d. 2001
Gratiot County
DeLong, Lillian F.  b. c 1857, d. c 1938
Raycraft, Burr  b. 1881, d. 1964
Raycraft, Elias H.  b. c 1863, d. 1918
Raycraft, John W.  b. 1886
Kalamazoo County
Marquette County
Beine, Janet Faith  b. 1930, d. 2015
Montcalm County
DeLong, Lillian F.  b. c 1857, d. c 1938
DeLong, Wilber  b. c 1848
Raycraft, Elias H.  b. c 1863, d. 1918
Unknown, Maggie  b. c 1850
Oakland County
Thompson, Barbara  b. 1929, d. 2016
Van Buren County
Prindle, Donna Jean  b. 1920, d. 2006
Washtenaw County
Dollinger, Samantha Jo  b. 1990, d. 2014
West, Brenda Cheryl  b. 1963, d. 1963
Wayne County
Bresbois, Bertha  b. 1910, d. 1953
Clark, Narcissa  b. 1906, d. 1991
Deaton, Kenneth Lee  b. 1948, d. 2016
Fite, James Thurston  b. 1908, d. 1988
Ham, Felix Gaines  b. 1884
Hessey, Juanita Dean  b. 1929, d. 1989
Hessey, Ward Murry  b. c 1898, d. 1957
Hunter, Beulah Cleopatra  b. 1896, d. 1974
Laine, Ester Clyde Jr.  b. 1924, d. 2012
Laine, Ester Clyde Sr.  b. 1898, d. 1970
Powers, Cledith Delene  b. 1929, d. 2017
Raycraft, Burr  b. 1881, d. 1964
Unknown, Carrie  b. c 1881
Minnesota
Bergan, Anton  b. c 1890, d. bt 1931 - 1939
Jordan, David Archie  b. 1932, d. 1994
Clay County
Burud, Mavis Ione  b. 1933, d. 2007
Jordan, David Archie  b. 1932, d. 1994
Dakota County
Engle, Dave  d. 2010
Douglas County
McIntyre, Anne Renfroe  b. 1868, d. 1927
Itasca County
Humphreys, Ruby Lee  b. 1911, d. 1994
Jordan, Edward Llewellyn  b. 1927, d. 1965
Jordan, Janice Ann  b. 1959, d. 2008
Jordan, Joyce Lee  b. 1958, d. 2002
McDaniel, Mary Sue  b. c 1940, d. 1965
Mower County
Bow, Judy Caroline  b. 1952, d. 2018
Norman County
Burud, Mavis Ione  b. 1933, d. 2007
Olmsted County
McDaniel, Lee Robert  b. 1943, d. 2005
St. Louis County
Burud, Mavis Ione  b. 1933, d. 2007
Todd County
Houst, Gloria A.  b. 1931, d. 2005
Wadena County
Jordan, Carlos Joseph  b. 1898, d. 1987
Winona County
Mississippi
Barrett, Samuel S.  b. 1839, d. 1910
Black, Aliston  b. 1846
Edwards, J.E.
Edwards, James Able  b. 1858, d. 1932
Harden, Eliza Jane  b. c 1848
Hatcher, Jennie  b. 1869, d. 1944
Kelley, L. Christopher  b. 1825, d. 1888
Keston, Julia M.  b. c 1872
King, Julian  b. 1809, d. 1848
King, Ratio Cannon  b. 1842, d. 1895
Martin, Nancy Elizabeth  b. 1978, d. 2022
McDaniel, James L.  b. 1849
Richardson, Ella  b. c 1860
Richardson, Frances  b. c 1844
Richardson, Franklin D.  b. c 1854
Richardson, Hiram  b. c 1819, d. b 1900
Richardson, Jason B.  b. c 1852
Richardson, Mathias  b. c 1848
Richardson, Nancy  b. 1846, d. 1932
Richardson, Ovay  b. c 1878
Richardson, Paxton O.  b. c 1866
Richardson, Peter H.  b. c 1845
Richardson, Richard W  b. c 1857
Richardson, Sarah  b. c 1842
Richardson, Tellie O.  b. a 1875
Ritchie, Mattie  b. c 1850
Slaughter, Nancy  b. c 1787
Smith, Marinda  b. 1820, d. 1897
Stone, Zenlda
Strube, Flora M  b. 1895
Strube, Harve H.  b. 1883
Strube, Irven  b. 1882
Strube, Jinnie L.  b. 1890
Strube, Lela  b. 1880
Strube, Mary Louisa  b. c 1847
Strube, Maud  b. 1886
Strube, Scena  b. c 1845
Strube, Shirley  b. 1897
Strube, Willie K.  b. 1892
Talbert, Charles David  b. 1864, d. 1938
Talbert, Samuel Ivan  b. c 1900, d. 1973
Terry, Nancy Ann  b. c 1785, d. b 1810
Terry, Thomas S.  b. c 1878
Unknown, Julia M.
Walker, Samuel Elkin  b. c 1816
Walton, Henry Lee Sr.  b. c 1886, d. 1970
Westfall, Samuel  b. c 1778, d. c 1852
Wortham, William Taliferro Jr.  b. 1806
Amite County
Westfall, Zachariah  b. 1810, d. 1877
Forrest County
Harrison County
Childers, Charlie Newton  b. 1894, d. 1920
Hinds County
Broom(e), Mittie E.  b. 1875, d. 1935
Mattox, Jessie  b. c 1849
Mattox, Nannie Lula  b. 1880, d. 1966
Reeves, Joseph H.  b. 1842, d. 1920
Welch, Nannie
Itawamba County
Jones County
Childers, Charlie Newton  b. 1894, d. 1920
LaFayette County
Smith, Bettie J.  b. 1859
Strube, Franklin  b. c 1849
Strube, James H.  b. 1856, d. 1923
Strube, Nancy M.  b. c 1852
Strube, Sallie  b. c 1857
Wortham, Sarah  b. 1803, d. 1875
Lamar County
Childers, Leslie Bolton  b. 1916, d. 1987
Lawrence County
Slaughter, Walter  b. c 1755, d. a 1826
Lee County
Marshall County
Milliken, James Stowers  b. 1901, d. 1982
Monroe County
Robertson, Johnny Berl  b. 1929, d. 2009
Pike County
Phillips, Hudson Kennard  b. 1910, d. 1968
Pontotoc County
Strube, James H.  b. 1856, d. 1923
Tishomingo County
Cobbs, Mary Louise  b. 1853, d. 1936
Reeves, Joseph H.  b. 1842, d. 1920
Wayne County
Jones, Fannie Gertrude  b. 1893, d. 1995
Lee, Catherine Elizabeth  b. 1875, d. 1966
Winston County
Talbert, Franklin D.  b. 1933, d. 1988
Talbert, Samuel Ivan  b. c 1900, d. 1973
Yazoo County
Gibbs, Barnett (Hon.)  b. 1851, d. 1904
Missouri
Alsbrook(s), Mattie  b. 1883
Busch, Sallie Marie  b. 1931, d. 2001
Darter, Tomas  b. c 1876
Darter, Wesley  b. c 1875
Hull, Mary Ann  b. 1834, d. 1908
Lambert, Gerard Barnes  b. 1886, d. 1967
Lambert, Jordan Wheat Jr.  b. 1878, d. 1917
Lambert, Marion L.J.  b. 1881, d. 1923
McClure, Mary Amanda  b. 1834
McGuire, Jessie Jo  b. 1871
Miller, Fanny  b. 1848
Milliken, Harriette Louisa  b. 1899, d. 1985
Milliken, Lillian Hord  b. 1888, d. 1973
Milliken, Madison John
Pyle, Susannah  b. 1786, d. 1861
Ramsey, Elizabeth  b. c 1843
Schumer, Danielle
Stafford, Della A.  b. 1877